French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

Toutes les annonces

    378773899
    25 octobre 2008

    CHARTRES ENROBES


    Greffe : chartres
    Référence de publication : BXC08294003179C - Annonce : 2168

    Depot au Bodacc publié le 25/10/2008

    Annonce n° 2168 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES route d'Illiers 28110 Luce - forme juridique : Société en nom collectif - depot : Comptes annuels et rapports

    Evénement : depot des comptes
    378773899
    09 octobre 2009

    CHARTRES ENROBES


    Greffe : chartres
    Référence de publication : BXC09267002491B - Annonce : 3186

    Depot au Bodacc publié le 09/10/2009

    Annonce n° 3186 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES route d'Illiers 28110 Luce - forme juridique : Société en nom collectif - depot : Comptes annuels et rapports

    Evénement : depot des comptes
    378773899
    24 juin 2010

    CHARTRES ENROBES


    Référence de publication : 20100121 - Annonce : 647

    Bodacc B n°20100121 publié le 24/06/2010

    Annonce n° 647 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Gérant(e) : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT (SNC) représenté par MORTAMET Bertrand Associé : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS (SAS) représenté par MORTAMET Bertrand Gérant associé : COLAS CENTRE OUEST (SA) représenté par BODY Serge Gérant associé : EUROVIA (SA) représenté par VAUTRAVERS Jean-Marc Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A (SA) Commissaire aux comptes suppléant : PAULET Bernard - Modification : Modification survenue sur l'administration

    Evénement : modifications
    378773899
    15 novembre 2010

    CHARTRES ENROBES


    Greffe : chartres
    Référence de publication : BXC10302003101S - Annonce : 3647

    Depot au Bodacc publié le 15/11/2010

    Annonce n° 3647 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES route d'Illiers 28110 Luce - forme juridique : Société en nom collectif - depot : Comptes annuels et rapports

    Evénement : depot des comptes
    378773899
    22 avril 2011

    CHARTRES ENROBES


    Référence de publication : 20110080 - Annonce : 302

    Bodacc B n°20110080 publié le 22/04/2011

    Annonce n° 302 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Gérant(e) : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT représenté par MORTAMET Bertrand Gérant associé : COLAS CENTRE OUEST représenté par VIDAL Jean Gérant associé : EUROVIA représenté par VAUTRAVERS Jean-Marc Associé : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS représenté par MORTAMET Bertrand Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A (SA) Commissaire aux comptes suppléant : PAULET Bernard - Modification : Modification survenue sur l'administration

    Evénement : modifications
    378773899
    17 octobre 2011

    CHARTRES ENROBES


    Greffe : chartres
    Référence de publication : BXC112770021633 - Annonce : 2989

    Depot au Bodacc publié le 17/10/2011

    Annonce n° 2989 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES route d'Illiers 28110 Luce - forme juridique : Société en nom collectif - depot : Comptes annuels et rapports

    Evénement : depot des comptes
    378773899
    01 février 2012

    CHARTRES ENROBES


    Référence de publication : 20120022 - Annonce : 308

    Bodacc B n°20120022 publié le 01/02/2012

    Annonce n° 308 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Gérant(e) : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT représenté par BISI Philippe Gérant associé : COLAS CENTRE OUEST représenté par VIDAL Jean Gérant associé : EUROVIA représenté par HURET François Associé : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS représenté par MORTAMET Bertrand Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A (SA) Commissaire aux comptes suppléant : PAULET Bernard - Modification : Modification survenue sur l'administration

    Evénement : modifications
    378773899
    30 octobre 2012

    CHARTRES ENROBES


    Greffe : chartres
    Référence de publication : BXC12292003433U - Annonce : 4190

    Depot au Bodacc publié le 30/10/2012

    Annonce n° 4190 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES route d'Illiers 28110 Luce - forme juridique : Société en nom collectif - depot : Comptes annuels et rapports

    Evénement : depot des comptes
    378773899
    11 janvier 2013

    CHARTRES ENROBES


    Greffe : greffe du tribunal de commerce de chartres
    Référence de publication : BXA13079001809S - Annonce : 367

    Bodacc A publié le 11/01/2013

    Annonce n° 367 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES Zone industrielle 28630 Gellainville Exploitation d'une centrale d'enrobage, de fabrication et de vente de matériaux d'enrobage. - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 15000 EUR - Administration : Gérant : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT représenté par BISI Philippe Gérant, Associé : COLAS CENTRE OUEST représenté par VIDAL Jean Gérant, Associé : EUROVIA représenté par HURET François Associé : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS Commissair - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : L'Action Républicaine - Opposition : au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance au siège social de la SOCIETE DES ENROBES DE BEAUCE Zone Industrielle Gellainville 28630 Chartres - Origine : acquis par achat au prix stipulé de 150000 Euros.

    Evénement : ventes et cessions
    378773899
    25 juillet 2013

    CHARTRES ENROBES


    Référence de publication : 20130142 - Annonce : 733

    Bodacc B n°20130142 publié le 25/07/2013

    Annonce n° 733 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Gérant : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT représenté par BISI Philippe Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : COLAS CENTRE OUEST (AFJ) représenté par GARNIER Patrick Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : EUROVIA représenté par HURET François Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A (SA) Commissaire aux comptes suppléant : PAULET Bernard - Modification : Modification survenue sur l'administration

    Evénement : modifications
    378773899
    04 novembre 2013

    CHARTRES ENROBES


    Greffe : chartres
    Référence de publication : 280111556400000 - Annonce : 2114

    Depot au Bodacc publié le 04/11/2013

    Annonce n° 2114 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES route d'Illiers 28110 Luce - forme juridique : Société en nom collectif - depot : Comptes annuels et rapports

    Evénement : depot des comptes
    378773899
    31 décembre 2014

    CHARTRES ENROBES


    Greffe : chartres
    Référence de publication : 280112759000000 - Annonce : 1978

    Depot au Bodacc publié le 31/12/2014

    Annonce n° 1978 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES route d'Illiers 28110 Luce - forme juridique : Société en nom collectif - depot : Comptes annuels et rapports

    Evénement : depot des comptes
    378773899
    15 septembre 2015

    CHARTRES ENROBES


    Greffe : chartres
    Référence de publication : 280113537300000 - Annonce : 2323

    Depot au Bodacc publié le 15/09/2015

    Annonce n° 2323 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES route d'Illiers 28110 Luce - forme juridique : Société en nom collectif - depot : Comptes annuels et rapports

    Evénement : depot des comptes
    378773899
    12 novembre 2015

    CHARTRES ENROBES


    Référence de publication : 20150218 - Annonce : 308

    Bodacc B n°20150218 publié le 12/11/2015

    Annonce n° 308 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Gérant : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT représenté par BISI Philippe Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : COLAS CENTRE OUEST (AFJ) représenté par GARNIER Patrick Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : EUROVIA représenté par HURET François Associé indéfiniment et solidairement responsable : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SACA) - Modification : Modification survenue sur l'administration

    Evénement : modifications
    378773899
    26 septembre 2016

    CHARTRES ENROBES


    Greffe : chartres
    Référence de publication : 280114709200000 - Annonce : 4044

    Depot au Bodacc publié le 26/09/2016

    Annonce n° 4044 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES route d'Illiers 28110 Luce - forme juridique : Société en nom collectif - depot : Comptes annuels et rapports

    Evénement : depot des comptes
    378773899
    03 janvier 2019

    CHARTRES ENROBES


    Greffe : chartres
    Référence de publication : 280100000282790 - Annonce : 1547

    Depot au Bodacc publié le 03/01/2019

    Annonce n° 1547 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES route d'Illiers 28110 Lucé - forme juridique : Société en Nom Collectif - depot : Comptes annuels et rapports

    Evénement : depot des comptes
    378773899
    24 octobre 2019

    CHARTRES ENROBES


    Greffe : chartres
    Référence de publication : 280100000390960 - Annonce : 1516

    Depot au Bodacc publié le 24/10/2019

    Annonce n° 1516 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES Route D'Illiers 28110 Lucé - forme juridique : Société en Nom Collectif - depot : Comptes annuels et rapports

    Evénement : depot des comptes
    378773899
    07 octobre 2021

    CHARTRES ENROBES


    Référence de publication : 20210196 - Annonce : 800

    Bodacc B n°20210196 publié le 07/10/2021

    Annonce n° 800 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES - forme juridique : Société en Nom Collectif - capital : - Administration : Modification de la désignation d'un dirigeant : gérant EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT Sté par actions simplifiée. Modification de la désignation d'un dirigeant : gérant COLAS CENTRE OUEST Sté par actions simplifiée. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de gérant Colas France Sté par actions simplifiée : GARNIER Patrick nom d'usage : GARNIER n'est plus représentant permanent; COUEGNAT Michel nom d'usage : COUEGNAT devient représentant permanent. Modification de la désignation d'un dirigeant : Associé en nom COLAS CENTRE OUEST Sté par actions simplifiée. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de Associé en nom Colas France Sté par actions simplifiée : GARNIER Patrick nom d'usage : GARNIER n'est plus représentant permanent; COUEGNAT Michel nom d'usage : COUEGNAT devient représentant permanent - Modification : Modification de l'administration.

    Evénement : modifications
    378773899
    30 décembre 2021

    CHARTRES ENROBES


    Référence de publication : 20210254 - Annonce : 721

    Bodacc B n°20210254 publié le 30/12/2021

    Annonce n° 721 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES - forme juridique : Société en Nom Collectif - capital : - Administration : SA à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.

    Evénement : modifications
    378773899
    03 février 2022

    CHARTRES ENROBES


    Référence de publication : 20220024 - Annonce : 1708

    Bodacc B n°20220024 publié le 03/02/2022

    Annonce n° 1708 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES - forme juridique : Société en Nom Collectif - capital : - Administration : Sté par actions simplifiée COLAS CENTRE OUEST n'est plus gérant. CANTIE Fabien nom d'usage : CANTIE devient gérant - Modification : Modification de l'administration.

    Evénement : modifications
    378773899
    10 février 2022

    CHARTRES ENROBES


    Référence de publication : 20220029 - Annonce : 112

    Bodacc B n°20220029 publié le 10/02/2022

    Annonce n° 112 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES - forme juridique : Société en Nom Collectif - capital : - Administration : Modification de la désignation d'un dirigeant : Associé en nom Colas France Sté par actions simplifiée - Modification : Modification de l'administration.

    Evénement : modifications
    378773899
    12 septembre 2023

    CHARTRES ENROBES


    Référence de publication : 20230175 - Annonce : 971

    Bodacc B n°20230175 publié le 12/09/2023

    Annonce n° 971 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES - forme juridique : Société en Nom Collectif - capital : - Administration : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de gérant EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT Sté par actions simplifiée : BISI Philippe nom d\'usage : BISI n\'est plus représentant permanent; VINTAER Jean nom d\'usage : VINTAER devient représentant permanent - Modification : Modification de l\'administration.

    Evénement : modifications
    378773899
    14 décembre 2023

    CHARTRES ENROBES


    Référence de publication : 20230241 - Annonce : 735

    Bodacc B n°20230241 publié le 14/12/2023

    Annonce n° 735 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES - forme juridique : Société en Nom Collectif - capital : - Administration : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de gérant EUROVIA Sté par actions simplifiée : HURET François nom d\'usage : HURET n\'est plus représentant permanent; SEGUIN Aymeric nom d\'usage : SEGUIN devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de Associé en nom EUROVIA : HURET François nom d\'usage : HURET n\'est plus représentant permanent; SEGUIN Aymeric nom d\'usage : SEGUIN devient représentant permanent - Modification : Modification de l\'administration.

    Evénement : modifications
    378773899
    11 février 2024

    CHARTRES ENROBES


    Référence de publication : 20240029 - Annonce : 624

    Bodacc B n°20240029 publié le 11/02/2024

    Annonce n° 624 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES - forme juridique : Société en Nom Collectif - capital : - Administration : Modification de la désignation d\'un dirigeant : gérant VINCI CONSTRUCTION Sté par actions simplifiée. Modification de la désignation d\'un dirigeant : Associé en nom VINCI CONSTRUCTION Sté par actions simplifiée. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de Associé en nom VINCI CONSTRUCTION Sté par actions simplifiée : SEGUIN Aymeric nom d\'usage : SEGUIN n\'est plus représentant permanent - Modification : Modification de l\'administration.

    Evénement : modifications
    378773899
    11 avril 2024

    CHARTRES ENROBES


    Référence de publication : 20240072 - Annonce : 750

    Bodacc B n°20240072 publié le 11/04/2024

    Annonce n° 750 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES - forme juridique : Société en Nom Collectif - capital : - Administration : - Modification : Nouveau siège.

    Evénement : modifications
    378773899
    15 septembre 2024

    CHARTRES ENROBES


    Référence de publication : 20240179 - Annonce : 619

    Bodacc B n°20240179 publié le 15/09/2024

    Annonce n° 619 N° RCS : 378773899 - Dénomination : CHARTRES ENROBES - forme juridique : Société en Nom Collectif - capital : - Administration : CANTIE Fabien nom d\'usage : CANTIE n\'est plus gérant. BRECHET Nicolas Yves Marie nom d\'usage : BRECHET devient gérant - Modification : Modification de l\'administration.

    Evénement : modifications