Toutes les annonces
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20080002 - Annonce : 1382
Bodacc B n°20080002 publié le 04/01/2008
Annonce n° 1382 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : PARKER Randall W radiation le 05 Décembre 2007. Président : VEILLE Jean-Marc en fonction le 05 Décembre 2007. - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20080047 - Annonce : 3398
Bodacc B n°20080047 publié le 19/03/2008
Annonce n° 3398 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ANONYME ERNST ET YOUNG AUDIT en fonction le 28 Juin 2000. Commissaire aux comptes suppléant : CARREGA Francois en fonction le 28 Juin 2000. Président : JOHNSON Lawrence modification le 17 Mars 2008. - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Greffe : pontoise
Référence de publication : BXC08034006417N - Annonce : 9328
Depot au Bodacc publié le 10/02/2009
Annonce n° 9328 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE 141 rue Michel Carre 95100 Argenteuil - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Greffe : pontoise
Référence de publication : BXC10006006799G - Annonce : 11147
Depot au Bodacc publié le 22/01/2010
Annonce n° 11147 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE 141 rue Michel Carre Immeuble Aristote 95100 Argenteuil - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Greffe : pontoise
Référence de publication : BXC11021007475E - Annonce : 14800
Depot au Bodacc publié le 07/02/2011
Annonce n° 14800 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE 141 rue Michel Carre Immeuble Aristote 95100 Argenteuil - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20110108 - Annonce : 1185
Bodacc B n°20110108 publié le 03/06/2011
Annonce n° 1185 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ANONYME ERNST ET YOUNG AUDIT en fonction le 28 Juin 2000 Président : JOHNSON Lawrence modification le 17 Mars 2008 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 25 Mai 2011 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Greffe : pontoise
Référence de publication : BXC11146015322D - Annonce : 12285
Depot au Bodacc publié le 10/06/2011
Annonce n° 12285 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE 141 rue Michel Carre Immeuble Aristote 95100 Argenteuil - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20110227 - Annonce : 884
Bodacc B n°20110227 publié le 24/11/2011
Annonce n° 884 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : S.A.S. - capital : - Administration : président : JOHNSON (Lawrence), commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ANONYME ERNST ET YOUNG AUDIT (SA), commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) - Modification : modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20120055 - Annonce : 956
Bodacc B n°20120055 publié le 18/03/2012
Annonce n° 956 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : président : STEPHENSON (Keith, Dwayne), directeur général : HEFFERON (Timothy, Ward), commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG AUDIT (SA), commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20120055 - Annonce : 957
Bodacc B n°20120055 publié le 18/03/2012
Annonce n° 957 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : président : STEPHENSON (Keith, Dwayne), directeur général délégué : HERZOG (Rolf), directeur général : HEFFERON (Timothy, Ward), commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG AUDIT (SA), commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20120202 - Annonce : 407
Bodacc B n°20120202 publié le 18/10/2012
Annonce n° 407 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : S.A.S. - capital : - Administration : président : STEPHENSON (Keith, Dwayne) ; directeurs généraux délégués : HERZOG (Rolf) et SCHWARTZ (Eric) ; directeur général : HEFFERON (Timothy, Ward) ; commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ANOMYNE ERNST ET YOUNG AUDIT (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Greffe : metz
Référence de publication : BDC130033003695 - Annonce : 120
Depot au Bodacc publié le 28/06/2013
Annonce n° 120 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE parc d'activités de Creutzwald, 2, rue de Saint-Omer 57150 Creutzwald - forme juridique : S.A.S. - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20140001 - Annonce : 1022
Bodacc B n°20140001 publié le 02/01/2014
Annonce n° 1022 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : SAS - capital : - Administration : président : STEPHENSON (Keith, Dwayne) ; directeurs généraux : GASPAR (Francisco), DE MIGUEL (Fernando) ; directeurs généraux délégués : HERZOG (Rolf), SCHWARTZ (Eric) ; commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ANONYME ERNST ET YOUNG AUDIT (SAh) ; commissaire aux comptes suppléant : AUDITEXT (SASh) - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Greffe : metz
Référence de publication : BDC14003900904C - Annonce : 250
Depot au Bodacc publié le 15/07/2014
Annonce n° 250 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE parc d'activités de Creutzwald, 2, rue de Saint-Omer 57150 Creutzwald - forme juridique : S.A.S. - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Greffe : metz
Référence de publication : BDC15002400221I - Annonce : 141
Depot au Bodacc publié le 21/03/2015
Annonce n° 141 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE parc d'activités de Creutzwald, 2, rue de Saint-Omer 57150 Creutzwald - forme juridique : S.A.S. - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Greffe : metz
Référence de publication : BDC16001600134Y - Annonce : 27
Depot au Bodacc publié le 06/02/2016
Annonce n° 27 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE parc d'activités de Creutzwald, 2, rue de Saint-Omer 57150 Creutzwald - forme juridique : S.A.S. - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20160046 - Annonce : 2694
Bodacc B n°20160046 publié le 06/03/2016
Annonce n° 2694 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : SAS - capital : 4000000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20160046 - Annonce : 2695
Bodacc B n°20160046 publié le 06/03/2016
Annonce n° 2695 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : SAS - capital : - Administration : président : STEPHENSON (Keith, Dwayne) ; directeurs généraux : GASPAR (Francisco), DE MIGUEL (Fernando) ; directeurs généraux délégués : SCHWARTZ (Eric), BROUX (Sylvain, Gabriel) ; commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ANONYME ERNST ET YOUNG AUDIT (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20160231 - Annonce : 541
Bodacc B n°20160231 publié le 27/11/2016
Annonce n° 541 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : SAS - capital : - Administration : président : STEPHENSON (Keith, Dwayne) ; directeurs généraux : JANSSEN-WEETZ (Pierre, Bruno), LAUER (Peter, Martin), GASPAR (Francisco), DE MIGUEL (Fernando) ; commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ANONYME ERNST ET YOUNG AUDIT (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Greffe : metz
Référence de publication : 016102100377117 - Annonce : 2496
Depot au Bodacc publié le 16/12/2016
Annonce n° 2496 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE 2 rue de Saint-Omer 57150 Creutzwald - forme juridique : SAS - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Greffe : metz
Référence de publication : 017092100451128 - Annonce : 2839
Depot au Bodacc publié le 10/10/2017
Annonce n° 2839 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE 2 rue Saint-Omer 57150 Creutzwald - forme juridique : SAS - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20170236 - Annonce : 1259
Bodacc B n°20170236 publié le 08/12/2017
Annonce n° 1259 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : SAS - capital : - Administration : président : STEPHENSON (Keith, Dwayne), directeurs généraux délégués : JANSSEN-WEETS (Pierre, Bruno), LAUER (Peter, Martin) ; directeurs généraux : GASPAR (Francisco), DE MIGUEL (Fernando) ; commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ANONYME ERNST ET YOUNG AUDIT (SA) - Modification : modification survenue sur l?administration
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20180098 - Annonce : 481
Bodacc B n°20180098 publié le 25/05/2018
Annonce n° 481 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : STEPHENSON Keith Dwayne ; Directeur général délégué : JANSSEN-WEETS Pierre, Bruno ; Directeur général : GASPAR Francisco ; Directeur général : DE MIGUEL Fernando ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ANOMYNE ERNST ET YOUNG AUDIT (SA) - Modification : Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/12/2017 : Partant : LAUER Peter, Martin, Directeur général délégué
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20180150 - Annonce : 1377
Bodacc B n°20180150 publié le 09/08/2018
Annonce n° 1377 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : STEPHENSON Keith, Dwayne ; Directeur général : GASPAR Francisco ; Directeur général : DE MIGUEL Fernando ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ANOMYNE ERNST ET YOUNG AUDIT (SA) - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Greffe : metz
Référence de publication : 575111166500000 - Annonce : 6506
Depot au Bodacc publié le 20/12/2018
Annonce n° 6506 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE 2 rue Saint-Omer 57150 Creutzwald - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Greffe : metz
Référence de publication : 575112153000000 - Annonce : 2809
Depot au Bodacc publié le 03/12/2019
Annonce n° 2809 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE 2 rue Saint-Omer 57150 Creutzwald - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20200236 - Annonce : 2060
Bodacc B n°20200236 publié le 04/12/2020
Annonce n° 2060 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : GASPAR Francisco ; Président : DE MIGUEL Fernando ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ANOMYNE ERNST ET YOUNG AUDIT (SA) - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20210016 - Annonce : 1505
Bodacc B n°20210016 publié le 24/01/2021
Annonce n° 1505 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GASPAR Francisco ; Directeur général : ESPARZA HERRAIZ Javier ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ANOMYNE ERNST ET YOUNG AUDIT (SA) - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Référence de publication : 20210217 - Annonce : 2048
Bodacc B n°20210217 publié le 07/11/2021
Annonce n° 2048 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : CLARK Patrick, Régis ; Directeur général : ESPARZA HERRAIZ Javier ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ANOMYNE ERNST ET YOUNG AUDIT (SA) - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCOOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
Greffe : metz
Référence de publication : 575116612300000 - Annonce : 5197
Depot au Bodacc publié le 24/07/2022
Annonce n° 5197 N° RCS : 389798927 - Dénomination : COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE 2 rue Saint-Omer 57150 Creutzwald - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptes