Toutes les annonces
JOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S.
Référence de publication : 20080022 - Annonce : 2232
Bodacc B n°20080022 publié le 01/02/2008
Annonce n° 2232 N° RCS : 304613912 - Dénomination : JOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S. - forme juridique : S.A.S. - capital : 11200000 EUR - Administration : départ du directeur général : MAJOR (John, David). - Modification : modification survenue sur l'administration. Date d'effet : 31/12/2006
Evénement : modificationsJOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S
Greffe : metz
Référence de publication : BDC090037004609 - Annonce : 49
Depot au Bodacc publié le 16/06/2009
Annonce n° 49 N° RCS : 304613912 - Dénomination : JOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S parc Saint Christophe, 10, avenue de l'Entreprise 95526 Cergy-Pontoise Cedex - forme juridique : S.A.S - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesJOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S
Greffe : metz
Référence de publication : BDC090077002372 - Annonce : 3
Depot au Bodacc publié le 14/10/2009
Annonce n° 3 N° RCS : 304613912 - Dénomination : JOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S Z.I. Nassau, 57150 Creutzwald - forme juridique : S.A.S - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesJOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S
Greffe : metz
Référence de publication : BDC10002600813W - Annonce : 5
Depot au Bodacc publié le 16/05/2010
Annonce n° 5 N° RCS : 304613912 - Dénomination : JOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S Z.I. Nassau, 57150 Creutzwald - forme juridique : S.A.S - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesJOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S
Greffe : metz
Référence de publication : BDC10007300134V - Annonce : 8
Depot au Bodacc publié le 08/10/2010
Annonce n° 8 N° RCS : 304613912 - Dénomination : JOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S Z.I. Nassau, 57150 Creutzwald - forme juridique : S.A.S - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesJOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S
Greffe : metz
Référence de publication : BDC110087001534 - Annonce : 2
Depot au Bodacc publié le 14/12/2011
Annonce n° 2 N° RCS : 304613912 - Dénomination : JOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S Z.I. Nassau, 57150 Creutzwald - forme juridique : S.A.S - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesJOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S.
Greffe : metz
Référence de publication : BDC12007500379D - Annonce : 8
Depot au Bodacc publié le 18/10/2012
Annonce n° 8 N° RCS : 304613912 - Dénomination : JOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S. Z.I. Nassau 57150 Creutzwald - forme juridique : S.A.S. - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesJOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S.
Greffe : metz
Référence de publication : BDC13004900113K - Annonce : 3
Depot au Bodacc publié le 17/08/2013
Annonce n° 3 N° RCS : 304613912 - Dénomination : JOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S. Z.I. Nassau 57150 Creutzwald - forme juridique : S.A.S. - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesJOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S
Référence de publication : 20140114 - Annonce : 961
Bodacc B n°20140114 publié le 17/06/2014
Annonce n° 961 N° RCS : 304613912 - Dénomination : JOHNSON CONTROLS CREUTZWALD S.A.S - forme juridique : SAS - capital : 56200000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital
Evénement : modificationsJOHNSON CONTROLS CREUTZWALD SAS
Référence de publication : 20140145 - Annonce : 644
Bodacc B n°20140145 publié le 31/07/2014
Annonce n° 644 N° RCS : 304613912 - Dénomination : JOHNSON CONTROLS CREUTZWALD SAS - forme juridique : SAS - capital : 570304 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital
Evénement : modificationsMOTUS CREUTZWALD SAS
Référence de publication : 20140204 - Annonce : 276
Bodacc B n°20140204 publié le 23/10/2014
Annonce n° 276 N° RCS : 304613912 - Dénomination : MOTUS CREUTZWALD SAS - forme juridique : SAS - capital : 20861126 EUR - Administration : président : VENTRIS (Alistair) ; directeur général : HECKEL (Clément) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS (Yves) - Modification : modification survenue sur la dénomination, le capital et l'administration
Evénement : modificationsMOTUS CREUTZWALD SAS
Greffe : metz
Référence de publication : 201605090421130 - Annonce : 5338
Depot au Bodacc publié le 01/06/2016
Annonce n° 5338 N° RCS : 304613912 - Dénomination : MOTUS CREUTZWALD SAS 57150 Creutzwald - forme juridique : SAS - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesMOTUS CREUTZWALD SAS
Référence de publication : 20170034 - Annonce : 2329
Bodacc B n°20170034 publié le 17/02/2017
Annonce n° 2329 N° RCS : 304613912 - Dénomination : MOTUS CREUTZWALD SAS - forme juridique : SAS - capital : - Administration : président : VENTRIS (Alistair) ; directeur général : HECKEL (Clément) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICE WHITEHOUSE COOPERS AUDIT (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU (Jean-Christophe) - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsMOTUS CREUTZWALD SAS
Greffe : metz
Référence de publication : 017012400471302 - Annonce : 3363
Depot au Bodacc publié le 18/04/2017
Annonce n° 3363 N° RCS : 304613912 - Dénomination : MOTUS CREUTZWALD SAS 57150 Creutzwald - forme juridique : SAS - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesMOTUS CREUTZWALD SAS
Greffe : metz
Référence de publication : 201709070034468 - Annonce : 4649
Depot au Bodacc publié le 14/09/2017
Annonce n° 4649 N° RCS : 304613912 - Dénomination : MOTUS CREUTZWALD SAS 57150 Creutzwald - forme juridique : SAS - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesMOTUS CREUTZWALD SAS
Référence de publication : 20180089 - Annonce : 1062
Bodacc B n°20180089 publié le 11/05/2018
Annonce n° 1062 N° RCS : 304613912 - Dénomination : MOTUS CREUTZWALD SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 4404619.61 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital ; OBJET DE LA FORMALITE : Réduction de capital à compter du 20/12/2017 ; Ancien : 20861126 EUR ; Nouveau : 4404619,61 EUR
Evénement : modificationsMOTUS CREUTZWALD SAS
Greffe : metz
Référence de publication : 575110596300000 - Annonce : 1519
Depot au Bodacc publié le 22/06/2018
Annonce n° 1519 N° RCS : 304613912 - Dénomination : MOTUS CREUTZWALD SAS 57150 Creutzwald - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesMOTUS CREUTZWALD SAS
Greffe : metz
Référence de publication : 062200334150008 - Annonce : 509
Depot au Bodacc publié le 30/06/2018
Annonce n° 509 N° RCS : 304613912 - Dénomination : MOTUS CREUTZWALD SAS Zone Industrielle Nassau 57150 Creutzwald - forme juridique : SAS - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesDAIMAY FRANCE SAS
Référence de publication : 20190097 - Annonce : 1377
Bodacc B n°20190097 publié le 21/05/2019
Annonce n° 1377 N° RCS : 304613912 - Dénomination : DAIMAY FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur la dénomination
Evénement : modificationsDAIMAY FRANCE SAS
Greffe : metz
Référence de publication : 575111969000000 - Annonce : 2426
Depot au Bodacc publié le 10/10/2019
Annonce n° 2426 N° RCS : 304613912 - Dénomination : DAIMAY FRANCE SAS 57150 Creutzwald - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesDAIMAY FRANCE SAS
Référence de publication : 20210066 - Annonce : 2105
Bodacc B n°20210066 publié le 04/04/2021
Annonce n° 2105 N° RCS : 304613912 - Dénomination : DAIMAY FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : HECKEL Clément ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsDAIMAY FRANCE SAS
Greffe : metz
Référence de publication : 575114863800000 - Annonce : 2683
Depot au Bodacc publié le 05/09/2021
Annonce n° 2683 N° RCS : 304613912 - Dénomination : DAIMAY FRANCE SAS 57150 Creutzwald - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesDAIMAY FRANCE SAS
Greffe : metz
Référence de publication : 575116458000000 - Annonce : 5616
Depot au Bodacc publié le 07/07/2022
Annonce n° 5616 N° RCS : 304613912 - Dénomination : DAIMAY FRANCE SAS 57150 Creutzwald - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesDAIMAY FRANCE SAS
Greffe : metz
Référence de publication : 5751MYG18221600 - Annonce : 2126
Depot au Bodacc publié le 08/09/2023
Annonce n° 2126 N° RCS : 304613912 - Dénomination : DAIMAY FRANCE SAS 57150 Creutzwald - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesDAIMAY FRANCE SAS
Référence de publication : 20240128 - Annonce : 2673
Bodacc B n°20240128 publié le 04/07/2024
Annonce n° 2673 N° RCS : 304613912 - Dénomination : DAIMAY FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : HECKEL Clément ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modifications